• DE
  • TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH - Julius-Saxler-Straße 7 54550 Daun Deutschland, Germany

Company Information

Company registration number
HRB11294 WITTLICH
Company Status
LIVE
Country
Germany
Registered Address
Julius-Saxler-Straße 7 54550 Daun Deutschland
Julius-Saxler-Straße 7 54550 Daun Deutschland DE

Management

Managing Directors
Michael Koch (Geschaeftsfuehrer)
Beatrix Anita Simon-Ludwig (Geschaeftsfuehrer)
Alfons Böhm (Geschaeftsfuehrer)
Company secretaries
Mirco Thomas Helbig (Prokura)
Officers
Mirco Thomas Helbig (Prokurist(in))
Grevenbroich
Beatrix Simon-Ludwig (Geschäftsführer(in))
Bausendorf
Michael Koch (Geschäftsführer(in))
Daun
Alfons Böhm (Geschäftsführer(in))
Tönisvorst
Stefan Künneke (Prokurist(in))
Paderborn
Stefan van der Sanden (Prokurist(in))
Duisburg

Company Details

Type of Business
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Incorporated
1975-11-13
Dissolved on
-
Age Of Company
1975-11-13 50 years
Activity
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Stahlrohrprodukten einschließlich Fittings, Flanschen, Ventilen und hiermit in Zusammenhang stehenden Produkten sowie mit anderen Stahlerzeugnissen, vornehmlich im Export und Import. Desweiteren gehören

Ownership

Share Capital
7500000 DEM

Jurisdiction Particularities

Additional Status Details
currently registered
-
-
Court
DE/Wittlich
Previous Names
TPS-Technitube Röhrenwerk GmbH
Legal Entity Identifier (LEI)
529900ZZ0P0YY2ANQW65
VAT Number
DE149933301
Website
http://www.tps-technitube.de
Email address
[email protected]
Phone
+49 65927120
Fax
+49 65921305

TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH Company Description

http://www.tps-technitube.de.
More information

Get TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract

You are here: Tps-Technitube Röhrenwerke Gmbh - Julius-Saxler-Straße 7 54550 Daun Deutschland, Germany

1975-11-13 50 years
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • years

Announcements from the Handelsregister

  • 2022-01-12 Modification
    • HRB *: TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun, Julius-Saxler- Str. *, D-* Daun. Prokura erloschen: Feltges, Rita, Salm, **. *.*.
    • 2021-09-02 Modification
      • HRB *: TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun, Julius-Saxler- Str. *, D-* Daun. Nicht mehr Geschäftsführer: Jäger, Matthias, Delbrück, **.*.*.
    • 2021-08-09 Modification
      • HRB *: TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun, Julius-Saxler- Str. *, D-* Daun. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Koch, Michael, Daun, **.*.*. Prokura erloschen: Dr. Koch, Michael, Sprockhövel, **.*.*.
  • Sign up to a plan to see the full content

    Did you know? kompany provides original and official company documents for TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH as filed with the government register. Guaranteed.

    Register Report

    Sample
    €7.20
    Add to Cart
     

    Official proof of the company existence

    Shareholder List

    Sample
    €7.20
    Add to Cart
     

    Details on the shareholders

    Articles of Association

    Sample
    €7.20
    Add to Cart
     

    Founding documents

    Annual Account

    Sample
    €15.20
    Add to Cart
     

    Financial data for the last reported full year

    Chronological Extract

    Sample
    €7.20
    Add to Cart
     

    Full record of registrable changes

    Official Filings

    Company filings direct from the official registry.

    • 2024-03-28 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 28.03.2024

      Add to Cart
       
    • 2024-03-08 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 08.03.2024

      Add to Cart
       
    • 2024-04-22 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 22.04.2024

      Add to Cart
       
    • 2024-03-04 - Anmeldung vom 04.03.2024

      Add to Cart
       
    • 2024-03-22 - Anmeldung vom 22.03.2024

      Add to Cart
       
    • 2024-05-14 - Anmeldung vom 14.05.2024

      Add to Cart
       
    • 2023-06-06 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 06.06.2023

      Add to Cart
       
    • 2023-06-12 - Anmeldung vom 12.06.2023

      Add to Cart
       
    • 2023-08-17 - Anmeldung vom 17.08.2023

      Add to Cart
       
    • 2021-06-25 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 25.06.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-08-23 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 23.08.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-12-23 - Anmeldung vom 23.12.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-07-06 - Vertretungsnachweis vom 06.07.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-06-25 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 25.06.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-08-23 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 23.08.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-07-01 - Anmeldung vom 01.07.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-08-26 - Anmeldung vom 26.08.2021

      Add to Cart
       
    • 2021-08-09 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 09.08.2021

      Add to Cart
       
    • 2020-01-29 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 29.01.2020

      Add to Cart
       
    • 2020-09-04 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 04.09.2020

      Add to Cart
       
    • 2020-03-06 - Vertretungsnachweis vom 06.03.2020

      Add to Cart
       
    • 2020-09-04 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 04.09.2020

      Add to Cart
       
    • 2020-09-04 - Anmeldung vom 04.09.2020

      Add to Cart
       
    • 2020-01-29 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 29.01.2020

      Add to Cart
       
    • 2020-01-31 - Anmeldung vom 31.01.2020

      Add to Cart
       
    • 2020-07-28 - Anmeldung vom 28.07.2020

      Add to Cart
       
    • 2019-01-25 - Anmeldung vom 25.01.2019

      Add to Cart
       
    • 2018-02-02 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 02.02.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-02-02 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 02.02.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-02-02 - Anmeldung vom 02.02.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-02-08 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 08.02.2018

      Add to Cart
       
    • 2017-01-26 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 26.01.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-08-30 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 30.08.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-12-21 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 21.12.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-12-21 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.12.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-12-21 - Anmeldung vom 21.12.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-01-26 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 26.01.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-08-30 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 30.08.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-02-02 - Anmeldung vom 02.02.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-09-05 - Anmeldung vom 05.09.2017

      Add to Cart
       
    • 2013-11-14 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 14.11.2013

      Add to Cart
       
    • 2013-11-14 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 14.11.2013

      Add to Cart
       
    • 2013-11-14 - Anmeldung vom 14.11.2013

      Add to Cart
       
    • 2012-07-17 - Anmeldung vom 17.07.2012

      Add to Cart
       
    • 2010-12-07 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 07.12.2010

      Add to Cart
       
    • 2010-12-07 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 07.12.2010

      Add to Cart
       
    • 2010-12-20 - Einwilligung oder Genehmigung vom 20.12.2010

      Add to Cart
       
    • 2010-10-15 - Anmeldung vom 15.10.2010

      Add to Cart
       
    • 2010-12-07 - Anmeldung vom 07.12.2010

      Add to Cart
       
    • 2010-12-07 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 07.12.2010

      Add to Cart
       
    • 2009-07-29 - Anmeldung vom 29.07.2009

      Add to Cart
       
    • 2007-04-18 - Anmeldung vom 18.04.2007

      Add to Cart
       

    expand_less